El Popular News

December 17, 2020

El Popular News - The largest Spanish language publication in Kern County and the San Joaquin Valley.

Issue link: https://www.ifoldsflip.com/i/1320556

Contents of this Issue

Navigation

Page 9 of 11

18 - 23 de Diciembre, 2020 © El Popular I 10A www.elpopularnews.com E ntre los retos que enfrenta el nuevo Gobierno está la derogación del Título 42, una normativa establecida por la Casa Blanca en marzo pasado que le permite a la Ofi cina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) expulsar extranjeros arrestados en la frontera argumentando una emer- gencia sanitaria por la COVID-19. Entre octubre y noviembre (los dos primeros meses del año fi scal de 2021), la CBP expulsó por la frontera sur del país a cerca de 120,000 inmigrantes echando mano del Titulo 42. Tatiana Broff, consultora para temas regionales de Women's Refugee Commission, resaltó que la inadecuada relación en- tre la pandemia, las solicitudes de asilo político y la seguridad fronteriza representa una complicada situación para que la nueva Administración pueda derogar esta regulación. M ientras hacía fi la en la terminal de Greyhound en la ciu- dad de Indio, en el Vale de Coachella, se le acercaron varios agentes federales vestidos de civil, le hicieron algunas preguntas y, poco después, lo esposaron y trasladaron a un centro de detención de inmigrantes. Solano fue puesto bajo proceso de deportación y en esa amargura transcurrieron casi tres años, hasta esta semana, cuando una corte de inmigración de Los Ángeles concluyó que los ofi ciales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) que lo arrestaron en 2018 se basaron en "su apariencia latina" y procedieron pues de forma ilegal. La corte, que ordenó poner fi n a los procedimientos de de- portación contra Solano, dijo en su fallo que, antes de que este fuera detenido, los ofi ciales "solo sabían su nombre, su lugar de residencia y su apariencia", pero que "estos no son factores apropiados para establecer el requisito de sospecha razona- ble". El fallo fue emitido por la Ofi cina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración, la instancia donde se apelan las deci- siones de las cortes migratorias, y un órgano dependiente del Departamento de Justicia. "Un ofi cial razonable de CBP debía saber que él o ella esta- ba violando la Cuarta Enmienda [de la Constitución, que prote- ge a las personas contra detenciones arbitrarias] al detenerlo solamente con base en su apariencia latina", dice el fallo. E l reporte presentado en el caso sobre el incumplimiento del Gobierno federal al Acuerdo Flores, que ordena a las autoridades migratorias no tener bajo su custodia a menores inmigrantes más de 20 días y garantizarles acceso a cuidados de salud y bienestar, entre otros, contiene las de- claraciones de varios adolescentes que aseguran fueron dro- gados a la fuerza. Los documentos judiciales contienen el testimonio de un ad- olescente mexicano que ingresó en octubre de 2019 de forma indocumentada al país en busca de refugio. El joven de 16 años le dijo a su abogada en noviembre pas- ado que había estado tomando alrededor de 20 pastillas de medicamento por día, y también habría sido inyectado. "Quiero irme porque cuando me enojo me ponen inyecciones", dijo. Al menos cinco veces le habrían puesto las inyecciones, la última el mes pasado, según describe el alegato. "Cuando me dan una inyección, me entristezco. Y luego duermo por un día. Cuando me despierto después, me siento desesperado. Mi cuerpo se siente desesperado", describe el joven, que vino buscando refugio al sentirse amenazado por pandilleros en México. Los abogados demandantes aseguraron que seis menores bajo la custodia de la Ofi cina de Reasentamiento de Refugia- dos (ORR) fueron retenidos indefi nidamente en el Nexus Chil- dren's Hospital en Houston, y al menos tres de ellos recibieron "medicación excesiva". Advierten que la pandemia podría hacer que Biden continúe con restricciones migratorias de Trump Se salva de la deportación inmigrante detenido en parada de bus de Greyhound "por su apariencia latina" Denuncian que menores indocumentados fueron sedados por 'La Migra' Defensores de los inmigrantes anticiparon que la pandemia de coronavirus se convierta en un obstáculo para que la Administración del presidente electo Joe Biden eche hacia atrás algunas de las regulaciones que el presidente Donald Trump impuso a inmigrantes en medio de la emergencia sanitaria. El 11 de enero de 2018, Edgar Solano, un inmigrante hispano que reside en California, tuvo que dirigirse a una parada de autobuses para regresar del trabajo, luego de que su auto sufriera una avería. Menores que cruzaron solos la frontera hacia EE.UU fueron sedados e inyectados a la fuerza mientras estaban bajo custodia del Gobierno del presidente Donald Trump, revelaron documentos judiciales presentados a un tribunal federal en Los Ángeles. AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA SOBRE EL PROYECTO DE PROGRAMA FEDERAL DE MEJORA DEL TRANSPORTE 2021, PROYECTO DE ENMIENDA 1 DEL PLAN REGIONAL DE TRANSPORTE 2018, Y ANÁLISIS DE CONFORMIDAD BORRADOR POR LA PRESENTE SE DA AVISO de que el Consejo de Gobiernos de Kern (Kern COG) llevará a cabo una audiencia pública a las 6:30 p.m. 21 de enero de 2021 en la oficina de Kern COG, 1401 19th Street, Suite 300, Bakersfield, CA 93301 con respecto al Borrador del Programa Federal de Mejoramiento del Transporte de 2021 (FTIP de 2021), el Borrador de la Enmienda 1 del Plan de Transporte Regional de 2018 (Enmienda 1 del RTP de 2018) y la correspondiente Proyecto de Análisis de Conformidad. La audiencia se lleva a cabo para recibir comentarios públicos. El FTIP 2021 es una lista a corto plazo de mejoras de capital y gastos operativos que utilizan fondos federales y estatales para proyectos de transporte en el condado de Kern durante los próximos cuatro años. El RTP 2018 es una estrategia a largo plazo para satisfacer las necesidades de transporte del condado de Kern hasta el año 2042. La Enmienda 1 contiene una actualización del proyecto para el área metropolitana de Bakersfield. El Análisis de conformidad correspondiente contiene la documentación que respalda la conclusión de que el FTIP 2021 y la Enmienda 1 del RTP 2018 cumplen con los requisitos de conformidad de la calidad del aire para el ozono y las partículas. Los esfuerzos de participación pública para el FTIP 2021 satisfacen los requisitos del programa de proyectos (POP) de la Administración Federal de Tránsito (FTA) para los fondos aplicables. Si no se reciben comentarios sobre el POP propuesto, el programa de tránsito propuesto será el programa final. Las personas con discapacidades pueden llamar a Kern COG al (661) 635-2900 con un aviso de 3 días hábiles por adelantado para solicitar las ayudas auxiliares necesarias para participar en la audiencia pública. Los servicios de traducción están disponibles (con un aviso de 3 días hábiles por adelantado) para participar hablando cualquier idioma con los servicios de traducción profesional disponibles. Un período de revisión y comentarios públicos de 30 días comenzará el 23 de diciembre de 2020 y concluirá el 22 de enero de 2021. Los documentos preliminares están disponibles para su revisión en la oficina de Kern COG y en el sitio web de Kern COG en www.kerncog.org. Los comentarios públicos son bienvenidos en la audiencia, o pueden enviarse por escrito antes de las 5 P.M. 22 de enero de 2021 a Ahron Hakimi en la siguiente dirección. De acuerdo con la Orden Ejecutiva N-29- 20 emitida por el Gobernador Newsom el 17 de marzo de 2020, la reunión pública estará disponible de forma remota. El enlace de la reunión y las instrucciones de accesibilidad se publicarán en el sitio web de Kern COG no menos de 72 horas antes de la reunión pública. FICTITIOUS BUSINESS NAME STATEMENT FILE No. 2020-B5142 G & F FOOTWEAR 401 FINLEY DR TAFT, CA 93268 Mailing Address: 401 FINLEY DR TAFT, CA 93268 This business is conducted by: INDIVIDUAL SIGNED: ARCELIA GOMEZ Last name of individual, partner, or name of Corporation, LLC or LP: ARCELIA GOMEZ 28129 CLYDESDALE AVE TAFT, CA 93268 The registrant commenced to transact business under the fictitious name or names listed above on: 12/01/2009. This Fictitious Business Name Statement expires five (5) years from date filed in the Office of the County Clerk, unless it expires earlier. The filing of this statement does not of itself authorize the use in this State of a Fictitious Business Name in violation of the rights of another under Federal State, or Common Law (See Section 14400 ET SEQ)., Business and Professions Code).This Statement filed with the County Clerk of Kern County on: 11/18/2020 Date Statement Expires: 11/18/2025 MARY B. BEDARD , CPA, Auditor-Controller-County Clerk County Clerk By: N. FRANCO December 11, 18, 25, 2020 / January 01, 2021 EL POPULAR FICTITIOUS BUSINESS NAME STATEMENT FILE No. 2020-B5360 SANDY'S LIL JELLY BEANS DAY CARE 3718 WENATCHEE AVE BAKERSFIELD, CA 93306 Mailing Address: 3718 WENATCHEE AVE BAKERSFIELD, CA 93306 This business is conducted by: INDIVIDUAL SIGNED: SANDRA RODRIGUEZ Last name of individual, partner, or name of Corporation, LLC or LP: SANDRA RODRIGUEZ 3718 WENATCHEE AVE BAKERSFIELD, CA 93306 The registrant commenced to transact business under the fictitious name or names listed above on: 11/30/2020 . This Fictitious Business Name Statement expires five (5) years from date filed in the Office of the County Clerk, unless it expires earlier. The filing of this statement does not of itself authorize the use in this State of a Fictitious Business Name in violation of the rights of another under Federal State, or Common Law (See Section 14400 ET SEQ)., Business and Professions Code).This Statement filed with the County Clerk of Kern County on: 12/07/2020 Date Statement Expires: 12/07/2025 MARY B. BEDARD , CPA, Auditor-Controller-County Clerk County Clerk By: M. HERNANDEZ December 18, 25, 2020 / January 01, 08, 2021 EL POPULAR FICTITIOUS BUSINESS NAME STATEMENT FILE No. 2020-B5395 THE BARNYARD FEED AND GRAIN 8001 HERMOSA RD BAKERSFIELD, CA 93307 Mailing Address: 12000 ALDERWOOD ST BAKERSFIELD, CA 93307 This business is conducted by: INDIVIDUAL SIGNED: FRANCISCO J. LEIDA Last name of individual, partner, or name of Corporation, LLC or LP: FRANCISCO JAVIER LEIDA 12000 ALDERWOOD ST BAKERSFIELD, CA 93307 The registrant commenced to transact business under the fictitious name or names listed above on: N/A . This Fictitious Business Name Statement expires five (5) years from date filed in the Office of the County Clerk, unless it expires earlier. The filing of this statement does not of itself authorize the use in this State of a Fictitious Business Name in violation of the rights of another under Federal State, or Common Law (See Section 14400 ET SEQ)., Business and Professions Code).This Statement filed with the County Clerk of Kern County on: 12/08/2020 Date Statement Expires: 12/08/2025 MARY B. BEDARD , CPA, Auditor-Controller-County Clerk County Clerk By: M. HERNANDEZ December 18, 25, 2020 / January 01, 08, 2021 EL POPULAR FICTITIOUS BUSINESS NAME STATEMENT FILE No. 2020-B5428 DIANA'S FLOWERS 4621 AUBURN ST BAKERSFIELD, CA 93306 Mailing Address: 4621 AUBURN ST BAKERSFIELD, CA 93306 This business is conducted by: INDIVIDUAL SIGNED: DIANA C. CASTANEDA Last name of individual, partner, or name of Corporation, LLC or LP: DIANA C. CASTANEDA 4621 AUBURN ST BAKERSFIELD, CA 93306 The registrant commenced to transact business under the fictitious name or names listed above on: N/A . This Fictitious Business Name Statement expires five (5) years from date filed in the Office of the County Clerk, unless it expires earlier. The filing of this statement does not of itself authorize the use in this State of a Fictitious Business Name in violation of the rights of another under Federal State, or Common Law (See Section 14400 ET SEQ)., Business and Professions Code).This Statement filed with the County Clerk of Kern County on: 12/09/2020 Date Statement Expires: 12/09/2025 MARY B. BEDARD , CPA, Auditor-Controller-County Clerk County Clerk By: N. FRANCO December 18, 25, 2020 / January 01, 08, 2021 EL POPULAR FICTITIOUS BUSINESS NAME STATEMENT FILE No. 2020-B5335 FILE No. 2020-B5336 KREATIONZ4U VALDEZ KREATIONZ 5417 MENSEN DR BAKERSFIELD, CA 93313 Mailing Address: 5417 MENSEN DR BAKERSFIELD, CA 93313 This business is conducted by: INDIVIDUAL SIGNED: MARTHA VALDEZ Last name of individual, partner, or name of Corporation, LLC or LP: MARTHA VALDEZ 5417 MENSEN DR BAKERSFIELD, CA 93313 The registrant commenced to transact business under the fictitious name or names listed above on: N/A . This Fictitious Business Name Statement expires five (5) years from date filed in the Office of the County Clerk, unless it expires earlier. The filing of this statement does not of itself authorize the use in this State of a Fictitious Business Name in violation of the rights of another under Federal State, or Common Law (See Section 14400 ET SEQ)., Business and Professions Code).This Statement filed with the County Clerk of Kern County on: 12/03/2020 Date Statement Expires: 12/03/2025 MARY B. BEDARD , CPA, Auditor-Controller-County Clerk County Clerk By: M. HERNANDEZ December 11, 18, 25, 2020 / January 01, 2021 EL POPULAR STATEMENT OF ABANDONMENT OF USE OF FICTITIOUS BUSINESS NAME FILE No. 2020-B3417 Business Name you wish to abandon: LA HACIENDA MARKET #2 1875 E. CALIFORNIA AVE. BAKERSFIELD, CA 93307 Mailing address of business: 1875 E. CALIFORNIA AVE. BAKERSFIELD, CA 93307 Registrant ( s) who wish to abandon the business name: QAED SALEH ALI 15800 CAFARO CT. BAKERSFIELD, CA 93314 SAMIR SHAIBI 6225 RIDGETOP TER BAKERSFIELD, CA 93306 After the statement is processed, it must be published once a week for four sucessive weeks, (publication to start within 30 days of the filing date and an affidavit of publication of the statement shall be filed with the County Clerk within 30 days after the completion of the publication.) (Original FBN Statement File Number: 2020-B3417 Original FBN Statement Filed on: 07/31/2020 This statement of Abandonment filed on: 11/25/2020 MARY B BEDARD, County Clerk N. FRANCO Published on: December 11, 18, 25, 2020 / January 01, 2021 EL POPULAR FICTITIOUS BUSINESS NAME STATEMENT FILE No. 2020-B5390 AGRACIANO CUEVAS TRUCKING 10904 SAN EMIDIO ST LAMONT, CA 93241 Mailing Address: 10904 SAN EMIDIO ST LAMONT, CA 93241 This business is conducted by: INDIVIDUAL SIGNED: AGRACIANO CUEVAS Last name of individual, partner, or name of Corporation, LLC or LP: AGRACIANO CUEVAS 10904 SAN EMIDIO ST LAMONT, CA 93241 The registrant commenced to transact business under the fictitious name or names listed above on: N/A . This Fictitious Business Name Statement expires five (5) years from date filed in the Office of the County Clerk, unless it expires earlier. The filing of this statement does not of itself authorize the use in this State of a Fictitious Business Name in violation of the rights of another under Federal State, or Common Law (See Section 14400 ET SEQ)., Business and Professions Code).This Statement filed with the County Clerk of Kern County on: 12/07/2020 Date Statement Expires: 12/07/2025 MARY B. BEDARD , CPA, Auditor-Controller-County Clerk County Clerk By: N. FRANCO December 18, 25, 2020 / January 01, 08, 2021 EL POPULAR FICTITIOUS BUSINESS NAME STATEMENT FILE No. 2020-B5130 SUNSHINE JANITORIAL SERVICES 5213 SILVER SPRINGS LN BAKERSFIELD, CA 93313 Mailing Address: 5213 SILVER SPRINGS LN BAKERSFIELD, CA 93313 This business is conducted by: GENERAL PARTNERSHIP SIGNED: OCTAVIO VILLARSENOR SANCHEZ Last name of individual, partner, or name of Corporation, LLC or LP: OCTAVIO VILLASENOR SANCHEZ 5213 SILVER SPRINGS LN BAKERSFIELD, CA 93313 SILVA SANCHEZ GONZALEZ 5213 SILVER SPRINGS LN BAKERSFIELD, CA 93313 The registrant commenced to transact business under the fictitious name or names listed above on: 05/01/2019 . This Fictitious Business Name Statement expires five (5) years from date filed in the Office of the County Clerk, unless it expires earlier. The filing of this statement does not of itself authorize the use in this State of a Fictitious Business Name in violation of the rights of another under Federal State, or Common Law (See Section 14400 ET SEQ)., Business and Professions Code).This Statement filed with the County Clerk of Kern County on: 11/17/2020 Date Statement Expires: 11/17/2025 MARY B. BEDARD , CPA, Auditor-Controller-County Clerk County Clerk By: R. ROBERTS-MARTIN December 11, 18, 25, 2020 / January 01, 2021 EL POPULAR

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of El Popular News - December 17, 2020