El Popular News

July 02, 2020

El Popular News - The largest Spanish language publication in Kern County and the San Joaquin Valley.

Issue link: http://www.ifoldsflip.com/i/1265885

Contents of this Issue

Navigation

Page 9 of 11

3 - 9 de Julio, 2020 © El Popular I 10A www.elpopularnews.com AVISOS LEGALES • LEGAL NOTICES FICTITIOUS BUSINESS NAME STATEMENT FILE No. 2020-B2634 G & W MFG. & WELDING 16132 WIDMERE RD. ARVIN, CA 93203 Mailing Address: P.O. BOX 158 ARVIN, CA 93203 This business is conducted by: CORPORATION SIGNED: WALTER EMBRY Last name of individual, partner, or name of Corporation, LLC or LP: BEAR MOUNTAIN MANUFACTURING AND WELDING, INCORPORATED 16132 WIDMERE RD. ARVIN, CA 93203 The registrant commenced to transact business under the fictitious name or names listed above on: 04/27/1987 . This Fictitious Business Name Statement expires five (5) years from date filed in the Office of the County Clerk, unless it expires earlier. The filing of this statement does not of itself authorize the use in this State of a Fictitious Business Name in violation of the rights of another under Federal State, or Common Law (See Section 14400 ET SEQ)., Business and Professions Code).This Statement filed with the County Clerk of Kern County on: 06/16/2020 Date Statement Expires: 06/16/2025 MARY B. BEDARD , CPA, Auditor-Controller-County Clerk County Clerk By: N. FRANCO June 26 / July 03, 10, 17, 2020 EL POPULAR FICTITIOUS BUSINESS NAME STATEMENT FILE No. 2020-B2658 EXCEL PERFORMANCE PEMF 16226 DOLLIE MAE CT BAKERSFIELD, CA 93314 Mailing Address: 16226 DOLLIE MAE CT BAKERSFIELD, CA 93314 This business is conducted by: MARRIED COUPLE SIGNED: STEVEN HATCHER Last name of individual, partner, or name of Corporation, LLC or LP: STEVEN HATCHER 16226 DOLLIE MAE CT BAKERSFIELD, CA 93314 SHELLEY HATCHER 16226 DOLLIE MAE CT BAKERSFIELD, CA 93314 The registrant commenced to transact business under the fictitious name or names listed above on: 05/27/2020 . This Fictitious Business Name Statement expires five (5) years from date filed in the Office of the County Clerk, unless it expires earlier. The filing of this statement does not of itself authorize the use in this State of a Fictitious Business Name in violation of the rights of another under Federal State, or Common Law (See Section 14400 ET SEQ)., Business and Professions Code).This Statement filed with the County Clerk of Kern County on: 06/17/2020 Date Statement Expires: 06/17/2025 MARY B. BEDARD , CPA, Auditor-Controller-County Clerk County Clerk By: M. HERNANDEZ June 26 / July 03, 10, 17, 2020 EL POPULAR Publicación de Todos Avisos Legales: emilio@elpopularnews.com • AV I S O S L E G A L E S • (Código Electoral Sección: 12112, 10510) POR LA PRESENTE SE DA AVISO que una elección tomará lugar en los siguientes Distritos el 3 de noviembre de 2020, con el propósito de elegir: A Miembros para la Junta Gobernante en los siguientes Distritos Escolares: (Los candidatos tienen que ser votantes inscritos que residan dentro del Distrito.) Las Declaraciones de Candidatura para los candidatos elegibles deseando presentar su candidatura se pueden obtener de la División de Elecciones, 1115 Truxtun Avenue, Bakersfield, comenzando el 13 de julio de 2020, 113 días antes de la elección, y se presentarán con la División de Elecciones a más tardar para las 5:00 p.m., el 7 de agosto de 2020, el día 88 antes de la elección. La ley actual requiere que todos los candidatos presenten una Declaración de Interés Económico (Formulario 700) con la división de elecciones del condado donde presentan su declaración de candidatura. Estos formularios se tienen que entregar a más tardar para la fecha final de la presentación de la declaración de candidatura. El formulario se puede encontrar en el sitio web FPPC (www.fppc.ca.gov), o está disponible en la División de Elecciones. Para obtener información con respecto a la presentación, llame a la División de Elecciones (661) 868-3590 o visite nuestro sitio web para el Manual de Candidatos en http://www.kernvote.com. En el caso de que no haya nominados o un número insuficiente de nominados para cada cargo y una petición para una elección no se presenta de manera oportuna, un nombramiento para tal cargo se hará conforme al Código Electoral Sección 10515. Cada candidato que se presenta para un cargo electivo no partidista puede preparar una Declaración del Candidato conforme a la Sección 13307 del Código Electoral. Tales declaraciones pueden incluir el nombre, la edad, y la ocu- pación del candidato y una breve descripción de no más de 200 palabras de la educación y las cualificaciones del candidato expresadas por el candidato. Cada declaración se incluirá en la Muestra de Boleta, que se envía por correo a cada votante. Se requerirá que cada candidato presentando una declaración pague por adelantado su parte prorrateada como condición de tener su declaración incluida en la Muestra de Boleta. Mary B. Bedard, CPA Auditora-Contralora-Secretaria del Condado Una copia de este aviso en español está disponible de la División de Elecciones, 1115 Truxtun Avenue, Bakersfield, CA 93301. Junta de Educación del Condado de Kern Distrito del Colegio Comunitario de Kern Distrito del Colegio Comunitario de West Kern Preparatoria Unión Conjunta de Delano Distrito Escolar Preparatoria de Kern Distrito Escolar Unión Preparatoria de Taft Distrito Escolar Unión Preparatoria de Wasco Distrito Escolar Unificado de El Tejon Distrito Escolar Unificado de Maricopa Distrito Escolar Unificado de McFarland Distrito Escolar Unificado de Mojave Distrito Escolar Unificado Conjunto de Muroc Distrito Escolar Unificado de Sierra Sands Distrito Escolar Unificado de Southern Kern Distrito Escolar Unificado de Tehachapi Distrito Escolar Unión de Arvin Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield Distrito Escolar de Beardsley Distrito Escolar de Belridge Distrito Escolar de Blake Distrito Escolar de Buttonwillow Distrito Escolar de Caliente Distrito Escolar Unión de Delano Distrito Escolar de Di Giorgio Distrito Escolar de Edison Distrito Escolar de Elk Hills Distrito Escolar de Fairfax Distrito Escolar de Fruitvale Distrito Escolar de General Shafter Distrito Escolar de Gorman Distrito Escolar Unión de Greenfield Distrito Escolar Unión de Kernville Distrito Escolar Unión de Lakeside Distrito Escolar de Lamont Distrito Escolar Unión de Linns Valley-Poso Flat Distrito Escolar Unión de Lost Hills Distrito Escolar de Maple Distrito Escolar de McKittrick Distrito Escolar de Midway Distrito Escolar de Norris Distrito Escolar de Panama-Buena Vista Distrito Escolar Unión de Pond Distrito Escolar de Richland Distrito Escolar de Rio-Bravo Greeley Distrito Escolar Unión de Rosedale Distrito Escolar de Semitropic Distrito Escolar Unión de South Fork Distrito Escolar de Standard Distrito Escolar de la Ciudad de Taft Distrito Escolar de Vineland Distrito Escolar Unión de Wasco Concejo Consultivo Municipal de Rosamond Distrito de Aeropuerto de Indian Wells Valley Distrito de Aeropuerto de Minter Field Puerto Aéreo y Espacial de Mojave Distrito de Servicios Comunitarios de Arvin Distrito de Servicios Comunitarios de Bear Valley Distrito de Servicios Comunitarios de Mountain Meadows Distrito de Servicios Comunitarios de Rosamond Distrito de Servicios Comunitarios de Stallion Springs Distrito de Cuidado de Salud de East Kern Distrito de Cuidado de Salud de Kern Valley Distrito de Cuidado de Salud de Muroc Distrito de Hospital de North Kern- South Tulare Distrito de Cuidado de Salud de Southwest Distrito de Cuidado de Salud de Tehachapi Valley Distrito de Cuidado de Salud de West Side Distrito de Irrigación de Shafter-Wasco Distrito de Servicios Públicos Municipales de Southern San Joaquin Distrito de Servicios Públicos de Frazier Park Distrito de Servicios Públicos de Lamont Distrito de Servicios Públicos de Mojave Distrito de Servicios Comunitarios de Desert Lake Distrito de Servicios Comunitarios de East Niles Distrito de Servicios Comunitarios de Golden Hills Distrito de Servicios Comunitarios de Inyokern Distrito de Recreo y Parques de Bear Mountain Distrito de Recreo y Parques de Buttonwillow Distrito de Recreo y Parques de McFarland Distrito de Recreo y Parques de Shafter Distrito de Servicios Públicos de Lost Hills Distrito Sanitario Núm. 1 de North of the River Agencia de Agua de Antelope Valley–East Kern Agencia de Agua del Condado de Kern Distrito de Agua de Greenfield Distrito de Agua de Indian Wells Valley Distrito de Agua de North Edwards Distrito de Agua Municipal de North of the River Distrito de Agua de las Comunidades de Rand Distrito de Agua de Tehachapi-Cummings Distrito de Agua de West Kern Distrito de Agua de Tormenta de Lamont AVISO DE LA ELECCIÓN PARA MIEMBROS DE LA JUNTA GOBERNANTE Los directores en los siguientes Distritos Especiales: (Los candidatos tienen que ser un elector residente dentro de la División del Distrito.) FICTITIOUS BUSINESS NAME STATEMENT FILE No. 2020-B2645 WIENERSCHNITZEL #184 2401 BRUNDAGE LN BAKERSFIELD, CA 93304 Mailing Address: 2401 BRUNDAGE LN BAKERSFIELD, CA 93304 This business is conducted by: INDIVIDUAL SIGNED: SAMUEL SANTIAGO Last name of individual, partner, or name of Corporation, LLC or LP: SAMUEL SANTIAGO 2401 BRUNDAGE LN BAKERSFIELD, CA 93304 The registrant commenced to transact business under the fictitious name or names listed above on: 06/01/2020 . This Fictitious Business Name Statement expires five (5) years from date filed in the Office of the County Clerk, unless it expires earlier. The filing of this statement does not of itself authorize the use in this State of a Fictitious Business Name in violation of the rights of another under Federal State, or Common Law (See Section 14400 ET SEQ)., Business and Professions Code).This Statement filed with the County Clerk of Kern County on: 06/17/2020 Date Statement Expires: 06/17/2025 MARY B. BEDARD , CPA, Auditor-Controller-County Clerk County Clerk By: M. HERNANDEZ July 03, 10, 17, 24, 2020 EL POPULAR FICTITIOUS BUSINESS NAME STATEMENT FILE No. 2020-B2664 VICTORIA NAILS & SPA 550 WOOLLOMES AVE., SUITE 104 DELANO, CA 93215 Mailing Address: 550 WOOLLOMES AVE., SUITE 104 DELANO, CA 93215 This business is conducted by: INDIVIDUAL SIGNED: TODD THUAT Last name of individual, partner, or name of Corporation, LLC or LP: TODD THUAT VAN 224 EMERALD PARKWAY DELANO, CA 93215 The registrant commenced to transact business under the fictitious name or names listed above on: N/A . This Fictitious Business Name Statement expires five (5) years from date filed in the Office of the County Clerk, unless it expires earlier. The filing of this statement does not of itself authorize the use in this State of a Fictitious Business Name in violation of the rights of another under Federal State, or Common Law (See Section 14400 ET SEQ)., Business and Professions Code).This Statement filed with the County Clerk of Kern County on: 06/18/2020 Date Statement Expires: 06/18/2025 MARY B. BEDARD , CPA, Auditor-Controller-County Clerk County Clerk By: R. ROBERTS-MARTIN July 03, 10, 17, 24, 2020 EL POPULAR FICTITIOUS BUSINESS NAME STATEMENT FILE No. 2020-B2774 FILE No. 2020-B2775 LAS MÁS LINDAS LAS MÁS LINDAS SHOP 6001 ALMENDRA AVE, APT. D BAKERSFIELD, CA 93309 Mailing Address: 6001 ALMENDRA AVE, APT. D BAKERSFIELD, CA 93309 This business is conducted by: INDIVIDUAL SIGNED: LINDA LARA Last name of individual, partner, or name of Corporation, LLC or LP: LINDA YVETTE LARA 6001 ALMENDRA AVE, APT. D BAKERSFIELD, CA 93309 The registrant commenced to transact business under the fictitious name or names listed above on: N/A . This Fictitious Business Name Statement expires five (5) years from date filed in the Office of the County Clerk, unless it expires earlier. The filing of this statement does not of itself authorize the use in this State of a Fictitious Business Name in violation of the rights of another under Federal State, or Common Law (See Section 14400 ET SEQ)., Business and Professions Code).This Statement filed with the County Clerk of Kern County on: 06/25/2020 Date Statement Expires: 06/25/2025 MARY B. BEDARD , CPA, Auditor-Controller-County Clerk County Clerk By: M. HERNANDEZ July 03, 10, 17, 24, 2020 EL POPULAR FICTITIOUS BUSINESS NAME STATEMENT FILE No. 2020-B2556 PAPE POWER SYSTEMS 34782 LENCIONI AVE. BAKERSFIELD, CA 93308 Mailing Address: 355 GOODPASTURE IS. RD. EUGENE, OR 97401 This business is conducted by: CORPORATION SIGNED: SETH SMYTHE Last name of individual, partner, or name of Corporation, LLC or LP: PAPE MATERIAL HANDLING, INC. 355 GOODPASTURE IS. RD. EUGENE, OR 97401 The registrant commenced to transact business under the fictitious name or names listed above on: 03/20/2020 . This Fictitious Business Name Statement expires five (5) years from date filed in the Office of the County Clerk, unless it expires earlier. The filing of this statement does not of itself authorize the use in this State of a Fictitious Business Name in violation of the rights of another under Federal State, or Common Law (See Section 14400 ET SEQ)., Business and Professions Code).This Statement filed with the County Clerk of Kern County on: 06/10/2020 Date Statement Expires: 06/10/2025 MARY B. BEDARD , CPA, Auditor-Controller-County Clerk County Clerk By: M. HERNANDEZ July 03, 10, 17, 24, 2020 EL POPULAR STATEMENT OF ABANDONMENT OF USE OF FICTITIOUS BUSINESS NAME FILE No. 2019-B7866 Business Name you wish to abandon: MIDTOWN FAMILY DENTISTRY 3500 TRUXTUN AVE BAKERSFIELD, CA 93301 Mailing address of business: 3500 TRUXTUN AVE BAKERSFIELD, CA 93301 Registrant ( s) who wish to abandon the business name: ME THOMAS DENTAL CORP. 13420 PERGOLA AVE BAKERSFIELD, CA 93314 After the statement is processed, it must be published once a week for four sucessive weeks, (publication to start within 30 days of the filing date and an affidavit of publication of the statement shall be filed with the County Clerk within 30 days after the completion of the publication.) (Original FBN Statement File Number: 2019-B7866 Original FBN Statement Filed on: 12/19/2019 This statement of Abandonment filed on: 06/25/2020 MARY B BEDARD, County Clerk M. HERNANDEZ Published on: July 03, 10, 17, 24, 2020 EL POPULAR STATEMENT OF ABANDONMENT OF USE OF FICTITIOUS BUSINESS NAME FILE No. 2019-B7867 Business Name you wish to abandon: JUST FOR KIDS AND FAMILY TOO! 3500 TRUXTUN AVE BAKERSFIELD, CA 93301 Mailing address of business: 3500 TRUXTUN AVE BAKERSFIELD, CA 93301 Registrant ( s) who wish to abandon the business name: ME THOMAS DENTAL CORP. 13420 PERGOLA AVE BAKERSFIELD, CA 93314 After the statement is processed, it must be published once a week for four sucessive weeks, (publication to start within 30 days of the filing date and an affidavit of publication of the statement shall be filed with the County Clerk within 30 days after the completion of the publication.) (Original FBN Statement File Number: 2019-B7867 Original FBN Statement Filed on: 12/19/2019 This statement of Abandonment filed on: 06/25/2020 MARY B BEDARD, County Clerk M. HERNANDEZ Published on: July 03, 10, 17, 24, 2020 EL POPULAR FICTITIOUS BUSINESS NAME STATEMENT FILE No. 2020-B2779 JUST FOR KIDS AND FAMILY TOO! DENTAL OFFICE OF ME THOMAS DENTAL CORP 3500 TRUXTUN AVE, SUITE A BAKERSFIELD, CA 93301 Mailing Address: 3500 TRUXTUN AVE, SUITE A BAKERSFIELD, CA 93301 This business is conducted by: CORPORATION SIGNED: MARK E. THOMAS, DDS Last name of individual, partner, or name of Corporation, LLC or LP: ME THOMAS DENTAL CORP. 13420 PERGOLA AVE BAKERSFIELD, CA 93314 The registrant commenced to transact business under the fictitious name or names listed above on: 06/01/2001 . This Fictitious Business Name Statement expires five (5) years from date filed in the Office of the County Clerk, unless it expires earlier. The filing of this statement does not of itself authorize the use in this State of a Fictitious Business Name in violation of the rights of another under Federal State, or Common Law (See Section 14400 ET SEQ)., Business and Professions Code).This Statement filed with the County Clerk of Kern County on: 06/25/2020 Date Statement Expires: 06/25/2025 MARY B. BEDARD , CPA, Auditor-Controller-County Clerk County Clerk By: M. HERNANDEZ July 03, 10, 17, 24, 2020 EL POPULAR FICTITIOUS BUSINESS NAME STATEMENT FILE No. 2020-B2780 MIDTOWN FAMILY DENTAL OFFICE, DENTAL OFFICE OF ME THOMAS DENTAL CORP 3500 TRUXTUN AVE, SUITE B BAKERSFIELD, CA 93301 Mailing Address: 3500 TRUXTUN AVE, SUITE B BAKERSFIELD, CA 93301 This business is conducted by: CORPORATION SIGNED: MARK E. THOMAS, DDS Last name of individual, partner, or name of Corporation, LLC or LP: ME THOMAS DENTAL CORP. 13420 PERGOLA AVE BAKERSFIELD, CA 93314 The registrant commenced to transact business under the fictitious name or names listed above on: 06/01/2000 . This Fictitious Business Name Statement expires five (5) years from date filed in the Office of the County Clerk, unless it expires earlier. The filing of this statement does not of itself authorize the use in this State of a Fictitious Business Name in violation of the rights of another under Federal State, or Common Law (See Section 14400 ET SEQ)., Business and Professions Code).This Statement filed with the County Clerk of Kern County on: 06/25/2020 Date Statement Expires: 06/25/2025 MARY B. BEDARD , CPA, Auditor-Controller-County Clerk County Clerk By: M. HERNANDEZ July 03, 10, 17, 24, 2020 EL POPULAR FICTITIOUS BUSINESS NAME STATEMENT FILE No. 2020-B2761 NEXT STEP CARDIO 506 CENTER ST TAFT, CA 93268 Mailing Address: 506 CENTER ST TAFT, CA 93268 This business is conducted by: INDIVIDUAL SIGNED: WENDY SOTO Last name of individual, partner, or name of Corporation, LLC or LP: WENDY SOTO 501 E ST TAFT, CA 93268 The registrant commenced to transact business under the fictitious name or names listed above on: 10/01/2008 . This Fictitious Business Name Statement expires five (5) years from date filed in the Office of the County Clerk, unless it expires earlier. The filing of this statement does not of itself authorize the use in this State of a Fictitious Business Name in violation of the rights of another under Federal State, or Common Law (See Section 14400 ET SEQ)., Business and Professions Code).This Statement filed with the County Clerk of Kern County on: 06/24/2020 Date Statement Expires: 06/24/2025 MARY B. BEDARD , CPA, Auditor-Controller-County Clerk County Clerk By: R. ROBERTS-MARTIN July 03, 10, 17, 24, 2020 EL POPULAR FICTITIOUS BUSINESS NAME STATEMENT FILE No. 2020-B2762 STUDIO X 661 4000 EASTON DR. #9 BAKERSFIELD, CA 93309 Mailing Address: 501 E ST TAFT, CA 93268 This business is conducted by: CO-PARTNERS SIGNED: WENDY SOTO Last name of individual, partner, or name of Corporation, LLC or LP: WENDY SOTO 501 E ST TAFT, CA 93268 ABRAHAM TRAVINO 201 COVERDALE CT BAKERSFIELD, CA 93307 The registrant commenced to transact business under the fictitious name or names listed above on: N/A . This Fictitious Business Name Statement expires five (5) years from date filed in the Office of the County Clerk, unless it expires earlier. The filing of this statement does not of itself authorize the use in this State of a Fictitious Business Name in violation of the rights of another under Federal State, or Common Law (See Section 14400 ET SEQ)., Business and Professions Code).This Statement filed with the County Clerk of Kern County on: 06/24/2020 Date Statement Expires: 06/24/2025 MARY B. BEDARD , CPA, Auditor-Controller-County Clerk County Clerk By: R. ROBERTS-MARTIN July 03, 10, 17, 24, 2020 EL POPULAR FICTITIOUS BUSINESS NAME STATEMENT FILE No. 2020-B2676 HGB TRUCKING 9612 WATER BURY DR BAKERSFIELD, CA 93312 Mailing Address: 9612 WATER BURY DR BAKERSFIELD, CA 93312 This business is conducted by: INDIVIDUAL SIGNED: HECTOR BAUTISTA Last name of individual, partner, or name of Corporation, LLC or LP: HECTOR BAUTISTA 9612 WATER BURY DR BAKERSFIELD, CA 93312 The registrant commenced to transact business under the fictitious name or names listed above on: N/A . This Fictitious Business Name Statement expires five (5) years from date filed in the Office of the County Clerk, unless it expires earlier. The filing of this statement does not of itself authorize the use in this State of a Fictitious Business Name in violation of the rights of another under Federal State, or Common Law (See Section 14400 ET SEQ)., Business and Professions Code).This Statement filed with the County Clerk of Kern County on: 06/18/2020 Date Statement Expires: 06/18/2025 MARY B. BEDARD , CPA, Auditor-Controller-County Clerk County Clerk By: M. HERNANDEZ July 03, 10, 17, 24, 2020 EL POPULAR FICTITIOUS BUSINESS NAME STATEMENT FILE No. 2020-B2771 KING SMOG 3123 EDISON HWY BAKERSFIELD, CA 93307 Mailing Address: 3123 EDISON HWY BAKERSFIELD, CA 93307 This business is conducted by: INDIVIDUAL SIGNED: JOSE GUADALUPE GALLARDO Last name of individual, partner, or name of Corporation, LLC or LP: JOSE GUADALUPE GALLARDO 1417 HUB AVE BAKERSFIELD, CA 93304 The registrant commenced to transact business under the fictitious name or names listed above on: N/A . This Fictitious Business Name Statement expires five (5) years from date filed in the Office of the County Clerk, unless it expires earlier. The filing of this statement does not of itself authorize the use in this State of a Fictitious Business Name in violation of the rights of another under Federal State, or Common Law (See Section 14400 ET SEQ)., Business and Professions Code).This Statement filed with the County Clerk of Kern County on: 06/25/2020 Date Statement Expires: 06/25/2025 MARY B. BEDARD , CPA, Auditor-Controller-County Clerk County Clerk By: M. HERNANDEZ July 03, 10, 17, 24, 2020 EL POPULAR "PRIMEX" VIENE de primera página solamente llegaron a oídos sordos. "Yo vi cuando metían a sorteado- ras a otro cuarto haciendo un espacio reducido" reclamó Carlos González, un operador de Primex. "Ellos no siguen las practicas de la distancia sana", agregando que en un cuarto donde deberían de haber no más de 18 personas, se encontraban con 24, no solamente reduciendo el espacio de trabajo, pero también no siguiendo las pautas de cuidado dadas por salubri- dad y por la CDC. Aunque los empleados de PRI- MEX no son miembros de la Union de Trabajadores Unidos (UFW), ellos reciben apoyo del sindicato, y durante una conferencia de prensa que tomó lugar en el medio ZOOM esta semana, empleados hablaron sobre las deman- das que han pedido de la empresa. Desafortunadamente, la empresa no ha sido muy buena en comunicándose con los empleados, especialmente du- rante el tiempo de la pandemia. Tal ha sido el problema que la empresa no se comunicó con los empleados cu- ando salieron los primeros contagios, es más no hicieron comentario ni si- quiera pusieron boletines, los mismos empleados tuvieron que tomar la tarea de informarse sobre quien y cuando salieron enfermos. Al organizarse, los empleados de Primex, empezaron a tomar un censo de si mismos para saber quien había resultado positivo, preguntando uno al otro, así recopilando una lista de aproximadamente 62 empleados de planta y temporales que están suf- riendo de esta enfermedad. Además, en la lista se agregaron los nombres de familiares de estos trabajadores que contrajeron la enfermedad, entre ellos un pequeñín de 9 meses de edad. Esta encuesta puede cambiar en cualquier momento, ya que no cuenta con los nombres de otros empleados que han tomado la prueba del COVID-19 y to- davía no saben sus resultados. Otro de los grandes problemas es que, si no eres empleado de planta, tu posición en la empresa, si es que te enfermas no es garantizada. "El De- partamento de Recursos Humanos te dice "tomate las dos semanas" pero cuando varios volvieron les dijeron que ya no trabajaban ahí" comentó Verónica Pérez, que es una sorteadora en la fabrica. PRIMEX cuenta con más de 400 empleados en esta facilidad, muchos de ellos son temporales. "Después de contagiarme, me dí cuenta que mis hijos estaban infecta- dos" dijo Marielos Cisneros, que tra- baja para la compañía, explicando que sus cuatro hijos estaban enfermos. "A mi me salieron una especie de granos en la piel, como si fuera una alergia", comentó la Sra. Cisneros. "Pero en re- alidad era parte de la enfermedad". "Se han hecho quejas a Cal OSHA y al Departamento de Salubridad del Condado" dijo Verónica Pérez. "Pero lo único que dicen es que van a in- vestigar, pero que no prometen nada". Aparte de estas dos entidades, no se han hecho quejas a entidades federa- les o estatales. En un comunicado de prensa, Mo- jgan Amin, CEO de PRIMEX Farms con sede en Los Angeles, dijo: "Recientemente, Primex ha exper- imentado que varios empleados dier- on positivo por el virus COVID-19. Desafortunadamente, un empleado que no siguió las pautas de Primex y viajó fuera de los Estados Unidos contrajo el virus. Como puede com- prender, Primex no puede controlar las circunstancias ni controlar lo que los empleados están haciendo afuera VEA "PRIMEX" página 12A

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of El Popular News - July 02, 2020